Avis de non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés

Le ministre des Finances a informé le directeur que les sociétés suivantes n’avaient pas respecté la Loi sur l’imposition des sociétés.

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(1) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés citées ci-dessous ne se conforment pas aux prescriptions énoncées par la Loi sur l’imposition des sociétés dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, lesdites sociétés se verront dissoutes par décision. Pour tout renseignement relatif au présent avis, veuillez vous adresser à l’Imposition des sociétés, ministère des Finances, 33, rue King ouest, Oshawa ON L1H 8H6.

DateDénomination sociale de la sociétéNuméro de la société en Ontario
2015-12-19

Ak Copy Centre Ltd.

001084784
2015-12-19

Americana Life Inc.

001754664
2015-12-19

Arcadian Home Decor Limited

002124864
2015-12-19

B. Green Recycling Inc.

002144807
2015-12-19

B.O.O.T. Truck Sales Inc.

001743095
2015-12-19

Blueskye Consulting Inc.

002106194
2015-12-19

Caletcordo Limited

001370247
2015-12-19

Camcar Products Inc.

000748656
2015-12-19

Canada Jia Zhou Yuan International Trade Corporation

002113578
2015-12-19

Canadian Shield Log Home Craftsmen Ltd.

001707597
2015-12-19

Cook’s Paralegal Services Ltd.

001696987
2015-12-19

Cusp Productions Inc.

001178687
2015-12-19

Davidson West Trading Company Ltd.

001162918
2015-12-19

Devitt Quarry Ltd.

001725060
2015-12-19

Diesel Training Studios Inc.

002126821
2015-12-19

Dollar General Canada Ltd.

002155516
2015-12-19

Don Williamson’s Hockey Power Canada Inc.

001740366
2015-12-19

DropN Go Ltd.

002139279
2015-12-19

Excent Care Products Inc.

002052674
2015-12-19

Falcor Productions Inc.

002000226
2015-12-19

Herdsman Plumbing & Heating Ltd.

001749117
2015-12-19

Heredia International Inc.

001678188
2015-12-19

I.G.S.T Enterprises Ltd.

001729159
2015-12-19

Igd Consulting Inc.

002033591
2015-12-19

Integrity Remodeling Corporation

002115102
2015-12-19

Intent Communications Inc.

001029320
2015-12-19

Jinpai Four Season Farm Group Inc.

001731915
2015-12-19

Kirk Of Collingwood Inc.

001469583
2015-12-19

Korner Kafe Ltd.

001390389
2015-12-19

La Petite Patisserie Inc.

001370903
2015-12-19

Lauder Lake Exploration Inc.

001734092
2015-12-19

Lawton Residential (1996) Ltd.

001157242
2015-12-19

Lexxco Mortgage Investment Corporation

001699571
2015-12-19

Lock Down Entertainment Management & Productions Inc.

001145655
2015-12-19

Logotech Marketing Inc.

002136870
2015-12-19

Loonie Car & Truck Rental Inc.

002103763
2015-12-19

Luz Cares Nanny Agency Inc.

002112064
2015-12-19

M Three Consulting Inc.

001310036
2015-12-19

M.L. Technologies Ltd.

001228447
2015-12-19

Maddy’s Country Grill Inc.

001716296
2015-12-19

Meck Enterprises Inc.

002103637
2015-12-19

Miya Realty Inc.

001311635
2015-12-19

Mo-Com Investments Limited

000243288
2015-12-19

Monaco C Lifestyles Corp.

002107922
2015-12-19

Mountainside Eatery Inc.

002094777
2015-12-19

Nad’s Embroidery Ltd.

002063199
2015-12-19

Nbco Holdings Inc.

001346755
2015-12-19

Olmat Truck Service Ltd.

001194606
2015-12-19

One St. Thomas Limited

000648132
2015-12-19

Papis Lounge Ltd.

001574716
2015-12-19

Pc Channels Corporation

000781604
2015-12-19

Qt Global Inc.

002124448
2015-12-19

R.S Mandi Construction Inc.

001713943
2015-12-19

Rdnlm Project Contract Management Limited

002110034
2015-12-19

Real-Eng Ltd.

001739859
2015-12-19

Revstone Industries Burlington Inc.

001722786
2015-12-19

Round Flag Construction Inc.

001747940
2015-12-19

Route 66 Oldies Cafe Ltd.

001704221
2015-12-19

Shamim Kanji Pharmacy Ltd.

001040539
2015-12-19

Tbo Bc Inc.

002145881
2015-12-19

Tf Nutrients Co.Td.

001753904
2015-12-19

Tg Norton Custom Creations Inc.

001707342
2015-12-19

The Concrete Depot Inc.

001285007
2015-12-19

The Manerwood Press Limited

001350397
2015-12-19

The Ronson Wilkinson Group Corporation

001181731
2015-12-19

Thrift Town (Four) Limited

001297885
2015-12-19

Trinet Systems Corporation

001113691
2015-12-19

Triple Star Computer Systems Consultants Ltd.

000849448
2015-12-19

V Sports Inc.

001677766
2015-12-19

Valentino Fine Homes Inc.

001640989
2015-12-19

Vanity Spas Inc.

002092360
2015-12-19

Watertec Restoration Services Inc.

001309379
2015-12-19

Weekenders Group International Inc.

002154440
2015-12-19

Whoolaginz Rag Company Ltd.

001068639
2015-12-19

Workforce International Employment Agency Inc.

002127868
2015-12-19

Worldlink Logistics Inc.

001699740
2015-12-19

1-800-File Tax Inc.

001278598
2015-12-19

1001272 Ontario Ltd.

001001272
2015-12-19

1009496 Ontario Corp.

001009496
2015-12-19

1083303 Ontario Limited

001083303
2015-12-19

1116366 Ontario Inc.

001116366
2015-12-19

1129114 Ontario Inc.

001129114
2015-12-19

125887 Ontario Limited

000125887
2015-12-19

1273771 Ontario Limited

001273771
2015-12-19

1291883 Ontario Limited

001291883
2015-12-19

1322603 Ontario Inc.

001322603
2015-12-19

1340069 Ontario Inc.

001340069
2015-12-19

1366645 Ontario Limited

001366645
2015-12-19

1431248 Ontario Limited

001431248
2015-12-19

1459939 Ontario Limited

001459939
2015-12-19

1508898 Ontario Inc.

001508898
2015-12-19

1520186 Ontario Inc.

001520186
2015-12-19

1557272 Ontario Inc.

001557272
2015-12-19

1610339 Ontario Inc.

001610339
2015-12-19

1648826 Ontario Limited

001648826
2015-12-19

1664402 Ontario Inc.

001664402
2015-12-19

1695523 Ontario Inc.

001695523
2015-12-19

1701354 Ontario Inc.

001701354
2015-12-19

1701474 Ontario Inc.

001701474
2015-12-19

1703507 Ontario Incorporated

001703507
2015-12-19

1706148 Ontario Inc.

001706148
2015-12-19

1720649 Ontario Ltd.

001720649
2015-12-19

1726378 Ontario Ltd.

001726378
2015-12-19

1738921 Ontario Inc.

001738921
2015-12-19

2049549 Ontario Inc.

002049549
2015-12-19

2092404 Ontario Inc.

002092404
2015-12-19

2110775 Ontario Ltd.

002110775
2015-12-19

2115670 Ontario Inc.

002115670
2015-12-19

2123658 Ontario Inc.

002123658
2015-12-19

2129892 Ontario Inc.

002129892
2015-12-19

2131765 Ontario Inc.

002131765
2015-12-19

2136052 Ontario Inc.

002136052
2015-12-19

2150129 Ontario Inc.

002150129
2015-12-19

2151766 Ontario Inc.

002151766
2015-12-19

2152450 Ontario Inc.

002152450
2015-12-19

2160576 Ontario Inc.

002160576
2015-12-19

439216 Ontario Limited

000439216
2015-12-19

517152 Ontario Limited

000517152
2015-12-19

817613 Ontario Inc.

000817613
2015-12-19

968953 Ontario Inc.

000968953

William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(148-G587)

Annulation de certificat de constitution (Non-observation de la Loi sur l’imposition des sociétés)

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(4) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de constitution de la société sous-nommé a été annulée par Ordre pour non-observation des dispositions de la Loi sur l’imposition des sociétés et que la dissolution de la société concernée prend effet à la date susmentionnée.

DateDénomination sociale de la sociétéNuméro de la société en Ontario
2015-11-23

A. Rao Management Consulting Inc.

001297338
2015-11-23

A.D. Nisbet Building Corporation

000931832
2015-11-23

Acton’s Inside Edge Pro Sports Inc.

002066107
2015-11-23

Advance System Design Manufacturing Ltd.

001703302
2015-11-23

Ag Powerlink Trading Inc.

001754597
2015-11-23

Allus Power Inc.

002121280
2015-11-23

Anthony’s Home Building Ltd.

001713252
2015-11-23

Beticas Corp.

001737244
2015-11-23

Blacktel Corporation

001037653
2015-11-23

Briarwood Building Systems Ltd.

001084459
2015-11-23

Bridgeport Services Group Inc.

001570174
2015-11-23

C. W. Mechanical Inc.

001003545
2015-11-23

Camtrek Resources Incorporated

000961845
2015-11-23

Ceramics Unlimited Inc.

001136294
2015-11-23

Cma Consulting Inc.

001379112
2015-11-23

Coffee Hut Inc.

001211664
2015-11-23

Countrywide Fuentes & Associates Inc.

001713801
2015-11-23

Dulsha Asset Management Inc.

001754771
2015-11-23

Earlee Cattle Drovers Inc.

000431468
2015-11-23

Ebola Records Inc.

002121504
2015-11-23

Endo Systems Inc.

001408768
2015-11-23

Exit To Paradise Inc.

001284989
2015-11-23

Face It Music Group Inc.

002147903
2015-11-23

Fashion Boutique Inc.

001289432
2015-11-23

Freightaway Xpress Inc.

001691159
2015-11-23

Ggr Mortgages Inc.

002148529
2015-11-23

Hassan Altaf Chartered Accountant Professional Corporation

002109938
2015-11-23

Ichiban Sushi House Inc.

001391336
2015-11-23

Impressive Promotions And Apparel Inc.

002008568
2015-11-23

Integrated Media Solutions Inc.

001729971
2015-11-23

Klaver Contracting Ltd.

001517986
2015-11-23

Kobak Custom Services Inc.

001418967
2015-11-23

Kordyban Holdings Inc.

002090337
2015-11-23

Manor House Holdings Inc.

001382328
2015-11-23

Manufacturers Service And Parts Sales Inc.

001194242
2015-11-23

Mecachrome Concepts & Design Inc.

001453451
2015-11-23

Megna Furniture Inc.

001461160
2015-11-23

Mortec Scientific Inc.

002120133
2015-11-23

Motor City Glass Ltd.

000777213
2015-11-23

Needlefish Entertainment Inc.

001724572
2015-11-23

Netfx Concepts Inc.

001246743
2015-11-23

North York Academy Of Golf & Practice Range Inc.

001226003
2015-11-23

Novoveo Ventures Inc.

002147092
2015-11-23

Oncard Media Inc.

001346449
2015-11-23

Ottawa Pro Baseball Inc.

002158700
2015-11-23

Pb Productions Inc.

002119514
2015-11-23

Peekamo Inc.

001719050
2015-11-23

Qsn Canada Inc.

002098962
2015-11-23

Quadrelle Realty Ltd.

001093621
2015-11-23

Quantum-Virtual Doctor Clinic21St CenturyInc.

001740821
2015-11-23

Reo Investor Rom Inc.

001202049
2015-11-23

Ri-Con Construction Company Limited

001753260
2015-11-23

Richmond Hill Education Inc.

002118497
2015-11-23

Rick’s Auto Glass Service Centre Ltd.

000772161
2015-11-23

Ringo Automotive Inc.

001688868
2015-11-23

Rowland Transport Inc.

001419442
2015-11-23

Security Depot Corp.

001644704
2015-11-23

Snugwood Resorts Inc.

001711860
2015-11-23

Starval Holdings Limited

000442613
2015-11-23

Superior North Shore Development Group Ltd.

001723048
2015-11-23

Tele-Teaching International Incorporated

000755745
2015-11-23

The Beacon Motor Hotel (Jordan) Limited

000094449
2015-11-23

Village Haven Cafe Inc.

002064661
2015-11-23

Westend Delivery Service Inc.

002035655
2015-11-23

Winterworks Snow And Ice Management Ltd.

001450978
2015-11-23

Yasmin Design Studioz Inc.

001718635
2015-11-23

Zuo Zhou Universal Trading Co., Ltd.

001442625
2015-11-23

1037137 Ontario Ltd.

001037137
2015-11-23

1119905 Ontario Limited

001119905
2015-11-23

1157154 Ontario Limited

001157154
2015-11-23

1170976 Ontario Inc.

001170976
2015-11-23

1181350 Ontario Inc.

001181350
2015-11-23

1196925 Ontario Ltd.

001196925
2015-11-23

1248454 Ontario Limited

001248454
2015-11-23

1301248 Ontario Ltd.

001301248
2015-11-23

1315344 Ontario Limited

001315344
2015-11-23

1328728 Ontario Limited

001328728
2015-11-23

1407055 Ontario Limited

001407055
2015-11-23

1462868 Ontario Inc.

001462868
2015-11-23

1584258 Ontario Inc.

001584258
2015-11-23

1586890 Ontario Inc.

001586890
2015-11-23

1618663 Ontario Limited

001618663
2015-11-23

1622119 Ontario Inc.

001622119
2015-11-23

1629749 Ontario Inc.

001629749
2015-11-23

1668014 Ontario Inc.

001668014
2015-11-23

1712231 Ontario Inc.

001712231
2015-11-23

1714879 Ontario Inc.

001714879
2015-11-23

1721933 Ontario Limited

001721933
2015-11-23

1722861 Ontario Inc.

001722861
2015-11-23

1727325 Ontario Inc.

001727325
2015-11-23

1738664 Ontario Inc.

001738664
2015-11-23

1738982 Ontario Inc.

001738982
2015-11-23

1741010 Ontario Inc.

001741010
2015-11-23

1749500 Ontario Inc.

001749500
2015-11-23

1754584 Ontario Inc.

001754584
2015-11-23

1757480 Ontario Ltd.

001757480
2015-11-23

2018221 Ontario Inc.

002018221
2015-11-23

2020742 Ontario Inc.

002020742
2015-11-23

2108113 Ontario Inc.

002108113
2015-11-23

2113772 Ontario Limited

002113772
2015-11-23

2113794 Ontario Inc.

002113794
2015-11-23

2114721 Ontario Inc.

002114721
2015-11-23

2117938 Ontario Inc.

002117938
2015-11-23

2118095 Ontario Inc.

002118095
2015-11-23

2119627 Ontario Inc.

002119627
2015-11-23

2119669 Ontario Inc.

002119669
2015-11-23

2121100 Ontario Inc.

002121100
2015-11-23

2126045 Ontario Inc.

002126045
2015-11-23

2126189 Ontario Inc.

002126189
2015-11-23

2133437 Ontario Inc.

002133437
2015-11-23

2134404 Ontario Incorporated

002134404
2015-11-23

2138987 Ontario Inc.

002138987
2015-11-23

2140206 Ontario Inc.

002140206
2015-11-23

2154423 Ontario Inc.

002154423
2015-11-23

2155052 Ontario Ltd.

002155052
2015-11-23

2161890 Ontario Inc.

002161890
2015-11-23

4 Stroke Offroad Gear Inc.

001573614

William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(148-G588)

Certificat de dissolution

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, un certificat de dissolution a été inscrit pour les compagnies suivantes. La date d’entrée en vigueur précède la liste des compagnies visées.

DateDénomination sociale de la sociétéNuméro de la société en Ontario
2015-11-06

Anu Trendz Inc.

001855127
2015-11-06

C.O.L. Holdings Ltd.

001071037
2015-11-06

Cooked Poultry Corporation

002270405
2015-11-06

Euro Trax Inc.

002171870
2015-11-06

Foy & Irene Incorporated

000668638
2015-11-06

H. A. Hollander Drugs Ltd.

001073357
2015-11-06

Hunter Financial Services Inc.

002197628
2015-11-06

Joannes Office Extra Inc.

002124119
2015-11-06

John Peressutti Tile Contractor Ltd.

000411373
2015-11-06

Mb Direct Home Services Inc.

002203943
2015-11-06

Polestar Shipping Canada Inc.

002366665
2015-11-06

Ps Transport Ltd.

002370104
2015-11-06

R&K Excavating Limited

001778755
2015-11-06

Sula Investments Limited

000211699
2015-11-06

Tony Schouten Service Centre Ltd.

000519550
2015-11-06

Varicon Productions Inc.

000657797
2015-11-06

Webezread Inc.

002313803
2015-11-06

Zeran Construction & Renovation Ltd.

000813180
2015-11-06

1375945 Ontario Limited

001375945
2015-11-06

1548643 Ontario Ltd.

001548643
2015-11-06

1610995 Ontario Inc.

001610995
2015-11-06

1649106 Ontario Inc.

001649106
2015-11-06

1810570 Ontario Ltd.

001810570
2015-11-06

2238341 Ontario Inc.

002238341
2015-11-06

2294265 Ontario Inc.

002294265
2015-11-06

2355666 Ontario Ltd.

002355666
2015-11-06

862155 Ontario Inc.

000862155
2015-11-06

989941 Ontario Inc.

000989941
2015-11-10

Adonyi Business Solutions Inc.

001165663
2015-11-10

Atherton & Sons Consulting Inc.

002317698
2015-11-10

Bourntec Solutions Inc.

002421830
2015-11-10

Dermco Limited

000617203
2015-11-10

Firenze Interiors Contracting Inc.

002296805
2015-11-10

Gold-Win Community Consultants Inc.

000609688
2015-11-10

Hirel Connections Inc.

002320776
2015-11-10

Ming Fashion Accessories Inc.

002135718
2015-11-10

Otoreke Holdings Ltd.

000883770
2015-11-10

Pacton Technologies Inc.

001538251
2015-11-10

Triumbaga Services Inc.

001692397
2015-11-10

Yhm Investments Inc.

001321659
2015-11-10

1802280 Ontario Ltd.

001802280
2015-11-10

2349386 Ontario Inc.

002349386
2015-11-10

2368948 Ontario Inc.

002368948
2015-11-10

903835 Ontario Limited

000903835
2015-11-11

All Niagara Insurance Brokers Inc.

000886874
2015-11-12

Munnaza Transportation Ltd.

002296000
2015-11-12

Serendipity Nails & Skin Care Inc.

001793528
2015-11-12

Sivas Corporation

002291810
2015-11-12

Vso Trans Inc.

001701127
2015-11-13

Brock Studios Inc.

002158585
2015-11-13

Hania Homes Inc.

002093139
2015-11-13

Integrity Chartered Accountant Inc.

002341471
2015-11-13

Paul J. Seys Ltd.

000927420
2015-11-13

1088109 Ontario Inc.

001088109
2015-11-13

1131923 Ontario Inc.

001131923
2015-11-13

1309360 Ontario Ltd.

001309360
2015-11-13

1732436 Ontario Inc.

001732436
2015-11-13

1852742 Ontario Inc.

001852742
2015-11-13

2065829 Ontario Ltd.

002065829
2015-11-16

Advancon Inc.

002000109
2015-11-16

Auto-Know Inc.

000878098
2015-11-16

Bereket Import Export Inc.

002263764
2015-11-16

Bill Fielding Haulage Inc.

001688497
2015-11-16

Central Cycle & Sports Inc.

000845052
2015-11-16

Crystal Line Ltd.

001192601
2015-11-16

Directive Personnel Inc.

001406940
2015-11-16

Dtscmo Ltd.

002165177
2015-11-16

Early Electric Limited

000455442
2015-11-16

Ellis Services Inc.

001219967
2015-11-16

Lz Steel Scrap Inc.

002247533
2015-11-16

M & Z Gas Bar And Convenience Store Ltd.

002146118
2015-11-16

Michael Stone Distribution Inc.

002239878
2015-11-16

Mmajjek Trucking Ltd.

000832879
2015-11-16

Nicolette Flemming And Associates Inc.

001175424
2015-11-16

Patton & Associates Inc.

001425863
2015-11-16

Quantum Driver Services Limited

001475931
2015-11-16

Rudy Driedger Farms Inc.

000701342
2015-11-16

Sales3 Inc.

002358057
2015-11-16

Shoemaker Mill Equipment Inc.

000298522
2015-11-16

Taste Of Turkey Inc.

002325584
2015-11-16

The Estates Of Kleinburg Ltd.

002015353
2015-11-16

Travel Information Network Inc.

000901029
2015-11-16

1070893 Ontario Inc.

001070893
2015-11-16

1197212 Ontario Inc.

001197212
2015-11-16

1663246 Ontario Inc.

001663246
2015-11-16

1702736 Ontario Inc.

001702736
2015-11-16

1855757 Ontario Limited

001855757
2015-11-16

2022901 Ontario Inc.

002022901
2015-11-16

2024642 Ontario Inc.

002024642
2015-11-16

2064296 Ontario Inc.

002064296
2015-11-16

2065835 Ontario Inc.

002065835
2015-11-16

2146331 Ontario Inc.

002146331
2015-11-16

2413346 Ontario Inc.

002413346
2015-11-16

657892 Ontario Limited

000657892
2015-11-16

736084 Ontario Ltd.

000736084
2015-11-16

948612 Ontario Inc.

000948612
2015-11-17

Cjs Accounting Services Inc.

001311848
2015-11-17

Daniel Quinn Detailing Inc.

001272250
2015-11-17

F And T Roofing Ltd.

001497047
2015-11-17

Granada Global Inc.

002234353
2015-11-17

Kcg Of Vaughan, Inc.

001605713
2015-11-17

M. Ransom Inc.

002168560
2015-11-17

Mirilee Incorporated

001787437
2015-11-17

Ottawa Stone Supply Ltd.

001850484
2015-11-17

Picture Me Perfect Inc.

001797127
2015-11-17

Shaka Management Inc.

001108618
2015-11-17

Straight Line Ii Performance Automotive Inc.

002226434
2015-11-17

Suzanne Lalonde Esthetics Inc.

000866497
2015-11-17

Working It! Making Your Clothes Work For You Inc.

002224560
2015-11-17

1211971 Ontario Inc.

001211971
2015-11-17

1632834 Ontario Limited

001632834
2015-11-17

1808219 Ontario Inc.

001808219
2015-11-17

1882708 Ontario Ltd.

001882708
2015-11-17

2009710 Ontario Inc.

002009710
2015-11-17

2186378 Ontario Corp.

002186378
2015-11-17

594461 Ontario Inc.

000594461
2015-11-17

818991 Ontario Inc.

000818991
2015-11-18

1730754 Ontario Limited

001730754
2015-11-18

2124891 Ontario Limited

002124891
2015-11-19

Canvasback North Inc.

001888632
2015-11-19

G. L. Statham Holdings Limited

001928361
2015-11-19

Smart Auto Check Ltd.

001777530
2015-11-19

1192386 Ontario Inc.

001192386
2015-11-19

1570001 Ontario Inc.

001570001
2015-11-20

Total Web Marketing Solutions Inc.

001851678
2015-11-20

671858 Ontario Inc.

000671858
2015-11-23

Norman Foster Refrigeration And Appliance Limited

000113386
2015-11-24

Slater Dental Hygiene Services Inc.

001782209
2015-11-24

247 Tech Inc.

002272917
2015-11-24

676618 Ontario Inc.

000676618
2015-11-24

952561 Ontario Inc.

000952561
2015-11-25

Joblanet Inc.

002361152
2015-11-25

Summit Communication Canada Inc.

002244232
2015-11-25

661352 Ontario Inc.

000661352
2015-11-26

Am Consulting Corporation

002281102
2015-11-26

Bojarski Ltd.

000420692
2015-11-26

Canadian Orthomolecular Biocentre Inc.

000987071
2015-11-26

Canadian Tire Holdings I Gp Inc.

002389906
2015-11-26

Change-Ability Inc.

001407026
2015-11-26

Douglas Calder Medicine Professional Corporation

002207729
2015-11-26

Gce Management Ltd.

001030271
2015-11-26

Hua Xia International (Canada) Ltd.

002043242
2015-11-26

J.M. Yaremovich & Associates Ltd.

000461635
2015-11-26

Jms Global Corporation

002043493
2015-11-26

Ken-Mar Property Holdings, Inc.

002043091
2015-11-26

Kremco Holdings Limited

001728580
2015-11-26

Meteorological & Environmental Planning Ltd.

000233475
2015-11-26

No-Nic Investments Ltd.

000732680
2015-11-26

On Site Electric Ltd.

000815159
2015-11-26

Panacolour Stucco Limited

002177987
2015-11-26

Penfund Mezzanine Management Inc.

001418302
2015-11-26

Poly-Layer Products Ltd.

000650635
2015-11-26

Promoteu Inc.

002334857
2015-11-26

Sb Law Professional Corporation

002271392
2015-11-26

Tendraland Training Inc.

001526392
2015-11-26

Trade Winds Air Conditioning Limited

000285237
2015-11-26

Uif Galaxy Gp Inc.

002191965
2015-11-26

World Tkd Academy Inc.

001785509
2015-11-26

Youssef Pharmacy Inc.

001543531
2015-11-26

1222144 Ontario Inc.

001222144
2015-11-26

2038008 Ontario Inc.

002038008
2015-11-26

2127479 Ontario Limited

002127479
2015-11-26

2397457 Ontario Inc.

002397457
2015-11-26

939795 Ontario Limited

000939795
2015-11-27

Aktuell Import Export Inc.

001204480
2015-11-27

Fantasesports Inc.

002345746
2015-11-27

G. C. Robinson Enterprises Inc.

000429700
2015-11-27

H & M Catering Inc.

001471313
2015-11-27

Huron Crossing Auto Inc.

002296643
2015-11-27

Jim Mclaren (Norwich) Limited

000294136
2015-11-27

Kit Innovations Inc.

002131534
2015-11-27

Lillah Enterprises Ltd.

001213619
2015-11-27

Marketech Solutions Consulting Inc.

002308874
2015-11-27

Outokumpu Mines Inc./Les Mines Outokumpu Inc.

001543280
2015-11-27

Rage Quit Media Inc.

002300067
2015-11-27

Royal Canadian Concept Inc.

001887664
2015-11-27

Tri-County Welding Supplies Limited

000204827
2015-11-27

Turtle Bins Inc.

002300595
2015-11-27

T1 Partnership Marketing Inc.

002062391
2015-11-27

Uba Uniforms Inc.

002066561
2015-11-27

Y&L Solutions Inc.

002139232
2015-11-27

1021934 Ontario Limited

001021934
2015-11-27

1513028 Ontario Ltd.

001513028
2015-11-27

1656206 Ontario Inc.

001656206
2015-11-27

1664835 Ontario Ltd.

001664835
2015-11-27

1817530 Ontario Inc.

001817530
2015-11-27

1825850 Ontario Inc.

001825850
2015-11-27

2069015 Ontario Limited

002069015
2015-11-27

2096604 Ontario Inc.

002096604
2015-11-27

2300293 Ontario Inc.

002300293
2015-11-27

2344767 Ontario Inc.

002344767
2015-11-27

404022 Ontario Limited

000404022
2015-11-27

755984 Ontario Limited

000755984
2015-11-30

Byng Yonge Holdings I Inc.

001242035
2015-11-30

Cimar Masonry Limited

000652378
2015-11-30

Dr. Donald James Pickett Chiropractic Professional Corporation

001686751
2015-11-30

Leo Potvin Limited

000236618
2015-11-30

M & M Golden Services Inc.

002114959
2015-11-30

Oberle Towers, Inc.

000635592
2015-11-30

Ontario’s Best Patio Cover Inc.

002441581
2015-11-30

P. & M. Luciani Ltd.

000364263
2015-11-30

Sandpiper Cove Ltd.

002061247
2015-11-30

Senior’s Deliveries Inc.

001426136
2015-11-30

Stiles Ltd.

002132118
2015-11-30

Suburg & Associates Inc.

002061898
2015-11-30

The Met Inc.

002053276
2015-11-30

Tim Mulvihill Drywalling And Painting Incorporated

000625322
2015-11-30

Triforte Building Corporation

002002066
2015-11-30

Zerofootprint Energy Inc.

002115591
2015-11-30

1268144 Ontario Inc.

001268144
2015-11-30

1297906 Ontario Inc.

001297906
2015-11-30

1527615 Ontario Inc.

001527615
2015-11-30

1795692 Ontario Inc.

001795692
2015-11-30

2104588 Ontario Limited

002104588
2015-11-30

2206209 Ontario Inc.

002206209
2015-11-30

2312247 Ontario Inc.

002312247
2015-11-30

2420004 Ontario Ltd.

002420004
2015-11-30

440162 Ontario Limited

000440162
2015-11-30

767207 Ontario Limited

000767207
2015-11-30

796065 Ontario Inc.

000796065
2015-12-01

Camerod Inc.

000957578
2015-12-01

College Of Certified Pedorthists Of Ontario Ltd.

002379920
2015-12-01

Comay Construction Ltd.

001643362
2015-12-01

Cornerstone Real Estate And Construction Inc.

002349967
2015-12-01

Dealer Service Systems Limited

000089785
2015-12-01

Great Southwestern Insurance Brokers Ltd.

000251749
2015-12-01

Hav-A-Java Inc.

001613347
2015-12-01

Hearth Wellness Inc.

002363344
2015-12-01

J. H. Stewart Developments Limited

001860151
2015-12-01

Kitsilano Trading Inc.

002472962
2015-12-01

Mddb Consulting Inc.

001687373
2015-12-01

Natural Creations Salon Corp.

002244373
2015-12-01

N4Rg Holdings Inc.

002455855
2015-12-01

N4Rg International Inc.

002455859
2015-12-01

Optrust Bcs Gp2 Inc.

002270755
2015-12-01

Shunyuan Food Inc.

002141221
2015-12-01

Stambler Incorporated

001040699
2015-12-01

The Cavuoti-Cavuoti Group Inc.

000358526
2015-12-01

2401247 Ontario Inc.

002401247
2015-12-01

893013 Ontario Inc.

000893013
2015-12-02

Caledonian Ventures Inc.

002232396
2015-12-02

Camenza Management (Ajax) Inc.

002290601
2015-12-02

Canadian Recycle Clothing Exporting Ltd.

001937757
2015-12-02

El Chinamo Latino Inc.

002250722
2015-12-02

Fjp Enterprises Inc.

001477310
2015-12-02

Hyland Limited

000303197
2015-12-02

J R C Investments Inc.

001209692
2015-12-02

Paul Yeung Inc.

001792032
2015-12-02

Puppiespaz Inc.

001672531
2015-12-02

Toronto Best Employment Agency Inc.

001911740
2015-12-02

2223081 Ontario Inc.

002223081
2015-12-02

2403745 Ontario Inc.

002403745

William D. Snell
Directeur, Ministère des Services gouvernementaux
(148-G589)

Avis de non-observation de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

Avis Est Donné Par La Présente que, conformément au paragraphe 241(3) de la Loi sur les sociétés par actions, si les sociétés mentionnées ci-dessous ne se conforment pas aux exigences de dépôt requises par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales dans un délai de 90 jours suivant la réception du présent avis, des ordonnances de dissolution seront délivrées contre lesdites sociétés.  La date d'entrée en vigueur précède la liste des sociétés visées.

DateDénomination sociale de la sociétéNuméro de la société en Ontario
2015-12-08

Lakewood Beach Properties Ltd.

1703352

William D. Snell
Directeur
(148-G590)

Annulation pour omission de se conformer à une obligation de dépôt (Loi sur les personnes morales)

Avis Est Donné Par La Présente que, les décrets émis en vertu de l’article 317 (9) de la Loi sur les personnes morales ont été émis pour annuler les lettres patentes des personnes morales suivantes et les déclarer dissoutes. La date du décret de la dissolution précède le nom de la personne morale.

DateDénomination sociale de la sociétéNuméro de la société en Ontario
2015-12-03

Brock Street Programs After Learning Daycare Of Kingston, Ontario

677765
2015-12-03

Women’s Integration Network Inc.

1881040
2015-12-04

The Alliston Masonic Temple Building Corporation

647517
2015-12-04

Your Voice For Bolton Inc.

1893501

William D. Snell
Directeur
(148-G591)

Commission de l'énergie de l'Ontario

Veuillez noter que cet avis n’a pas été publié en français.

Taux d’indexation de 2016, franchises et montants révisés pour l’assurance-automobile en vertu de la Loi sur les assurances et de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales – Accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er  novembre 1996 (Aial)

Taux D’Indexation

Disposition de la Loi sur les assurancesDescriptionMontant2015Montant2016
268.1Taux d’indexation2,0 %1,0 %

Franchise

Disposition de la Loi sur les assurancesDescriptionMontant2015Montant2016
267.1 (8) 3Franchise pour perte non pécuniaire14 700,27 $14 847,27 $
 Franchise en vertu de la Loi sur le droit de la famille7 350,15 $7 423,65 $

Montants

Disposition de l'AialDescriptionMontant2015Montant2016
10 (9)Montant maximal d’une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu**1 483,41 $1 498,24 $
15 (5)Rémunération hebdomadaire moyenne pour l’Ontario938,69 $962,12 $
16 (1) a)Indemnités forfaitaires pour chaque année d’études élémentaires2 966,75 $2 996,42 $
16 (1) b)Indemnités forfaitaires pour chaque année d’études secondaires**5 933,51 $5 992,85 $
16 (1) b)Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études secondaires**2 966,75 $2 996,42 $
16 (1) c)Indemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études postsecondaires**11 867,06 $11 985,73 $
16 (1) cIndemnités forfaitaires pour chaque trimestre d’études postsecondaires**5 933,51 $5 992,85 $
18 (5)Montant d’une indemnité hebdomadaire de soignant pour la première personne370,83 $374,54 $
18 (5)Montant d’une indemnité hebdomadaire de soignant par personne supplémentaire74,12 $74,86 $
28 (4)Montant maximal de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain1 483,41 $1 498,24 $
32 (5)Somme maximale des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain et du supplément hebdomadaire1 483,41 $1 498,24 $
46 (1)Montant maximal des indemnités complémentaires pour frais médicaux et des indemnités de réadaptation **1 483 379,20 $1 498 212,99 $
47 (4)Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (toutes les personnes assurées)4 450,14 $4 494,64 $
47 (5)Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (déficiences invalidantes)8 900,28 $8 989,28 $
47 (6)Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (multiples lésions, déficiences invalidantes)14 833,78 $14 982,12 $
47 (7)Montant maximal mensuel des indemnités de soins auxiliaires (graves lésions au cerveau qui entraînent un comportement violent)14 833,78 $14 982,12 $
50 (6)Taux horaire pour soins auxiliaires personnels (selon la formule 1)12,98 $13,11 $
50 (6)Taux horaire pour soins auxiliaires qualifiés (selon la formule 1)20,76 $20,97 $
51 (1) b)Prestations de décès si la personne assurée ne répondait à aucun des critères d’admissibilité à l’indemnité de remplacement de revenu74 168,94 $74 910,63 $
51 (4) a)Prestations de décès à une personne à la charge14 833,78 $14 982,12 $
51 (4) b)Prestations de décès à l’ancien conjoint14 833,78 $14 982,12 $
51 (5)Prestations de décès si l’assuré était une personne à charge14 833,78 $14 982,12 $
51 (8)Montant minimal des prestations de décès au conjoint74 168,94 $74 910,63 $
51 (8)Montant maximal des prestations de décès au conjoint296 675,84 $299 642,60 $
52 (2)Indemnités funéraires8 900,28 $8 989,28 $
54 (4)Frais hebdomadaires pour s’occuper de la première personne à charge111,25 $112,36 $
54 (4)Frais hebdomadaires pour s’occuper de chaque personne à charge supplémentaire37,10 $37,47 $
54 (5)Montant maximal pour les frais hebdomadaires de soins aux personnes à charge222,50 $224,73 $

**Le surintendant continue d’indexer ces montants comme l’exige la loi. Cependant, certains montants indexés (comme indiqué par deux astérisques sur le tableau) ne sont plus pertinents dans certains cas. Veuillez consulter les dispositions applicables du projet de loi 164–Annexe sur les indemnités d’accident légales pour savoir si ces montants indexés s’appliquent à votre situation.

(148-G593F)

Seuils monétaires et franchises – 2016 Indemnités pour perte non pécuniaire accordée en vertu de la Loi sur les assurances et au terme d’une action en justice à la suite d’un accident d’automobile survenu le 1er novembre 1996 ou après cette date (règlement de l’Ontario 461/96)

Seuils Monétaires

Paragraphe en cause dans la 
Loi sur les assurances

Description

Montants du 1eraoût au 
31 décembre 2015

Montants de 2016

267.5(8.3)

Perte non pécuniaire

121799$

123016,99 $

267.5(8.4)

Action en vertu de la Loi sur le droit de la famille

60899$

61507,99$

Deductible Amounts

Paragraphe en cause pour les instances judiciaires portant sur les accidents d’automobile survenus le 1ernovembre 1996 ou après cette date 
(Règl. de l’Ont.’461/96)

Description

Montants du 1eraoût au 
31 décembre 2015

Montants de 2016

5.1(1)

Franchise lors de perte non pécuniaire

36540$

36905,40$

5.1(2)

Franchise dans le cadre de la Loi sur le droit de la famille

18270$

18452,70$

(148-G594F)

Loi sur le marriage

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 21 septembre 2015 au 25 septembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Caldwell, Eileen PatriciaLakefield, ON21-Sep-15
Jones, ChristianLakefield, ON21-Sep-15
Amanquah, Davis QNorth York, ON21-Sep-15
Allard, Paul JCochrane, ON21-Sep-15
Jangam, Philip JScarborough, ON21-Sep-15
Bateman, Catherine ETrenton, ON21-Sep-15
MacDouell, SteveLondon, ON22-Sep-15
Askwith, JonathanOttawa, ON22-Sep-15
Pacarynuk, LisaOttawa, ON22-Sep-15
Keenan, WilliamHamilton, ON22-Sep-15
Armstrong, Jean RThunder Bay, ON22-Sep-15
D’Addurno, AnthonyLoretto, ON22-Sep-15
Harden, ChristinaTecumseh, ON22-Sep-15
Maissner, Benjamin ZeevToronto, ON22-Sep-15
Richards, Tracy BToronto, ON22-Sep-15
Ndirangu, Eunice WScarborough, ON22-Sep-15
Ndirangu, Samuel MScarborough, ON22-Sep-15
Trask, Noah AlbertKingston, ON22-Sep-15
Mendes de Moura, CatianeBurlington, ON23-Sep-15
Bankole, Sandra TBowmanville, ON23-Sep-15
Smith, Gregory WayneEganville, ON23-Sep-15
Chun, Joon BumThornhill, ON23-Sep-15
Hubert, NikolausBrockville, ON24-Sep-15
Wells, Judith AToronto, ON24-Sep-15
Girzewska, IlonaMississauga, ON24-Sep-15
Hodgson, RaymondSarnia, ON24-Sep-15
Hodgson, Cathering JoyceSarnia, ON24-Sep-15
Savurimuthu, Arokia DossBlenheim, ON24-Sep-15
Swiatoschuk, SylviaBelle River, ON25-Sep-15
Craig, D. ChrisGriffith. ON25-Sep-15
Craig, SonjaGriffith. ON25-Sep-15

Réinscriptions

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Adeosun, David OGuelph, ON22-Sep-15
Seales, Leslie ACollingwood, ON23-Sep-15

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 21 septembre 2015 au 25 septembre 2015

DateNomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Du 8 octobre 2015 au 12 octobre 2015Bice, Stephen DBelleville, ON24-Sep-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 21 septembre 2015 au 25 septembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
McKay, Matthew JohnToronto, ON21-Sep-15
Penner, JacobSt. Williams, ON22-Sep-15
Irwin-Gibson, Mary CatherineKingston, ON24-Sep-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G595)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Persaud, Justin PWhitby, ON28-Sep-15
Dupuis, Michelle MarieLively, ON28-Sep-15
Funelas, John EWarkworth, ON28-Sep-15
LeFave, JonathanToronto, ON28-Sep-15
Lyons, CharlesHuntsville, ON28-Sep-15
Campbell, Alan AndrewLondon, ON28-Sep-15
Limos, Efren SErin, ON28-Sep-15
Vetro, VincenzoGeorgetown, ON29-Sep-15
Paucar, HeinnerHamilton, ON29-Sep-15
Jones, Robin PatriciaWestport, ON29-Sep-15
Chambers, MaxBrampton, ON29-Sep-15
Johnson, Bradley LLondon, ON30-Sep-15
Yong, Damasus Piew TeingMississauga, ON30-Sep-15
Beaublanc, Jean Marie DennyToronto, ON30-Sep-15
Baldwin, Judi RBurlington, ON30-Sep-15
Carruthers, Cheryll JColdwater, ON30-Sep-15
Murkin, Catherine AnnKirkland, ON30-Sep-15
Lim, James CToronto, ON30-Sep-15
Simon, John P.Hamilton, ON30-Sep-15
O’Brien, Michael JSt. Thomas, ON30-Sep-15
Sullivan, Eric P.B.Toronto, ON30-Sep-15

Réinscriptions

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Doerr, Robert ETillsonburg, ON29-Sep-15
Hunter, Pamela ElaineBrampton, ON30-Sep-15

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2015

DateNomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Du 17 juin 2016 au 21 juin 2016Wiseman, Rowena JSt. John’s, NB29-Sep-15
Du 22 octobre 2015 au 26 octobre 2015Mattiasson,Terri-AnnChesley, ON30-Sep-15
Du 5 novembre 2015 au 9 novembre 2015Aldred, MichaelBurlington, ON30-Sep-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Bain, AlbertKingston, ON28-Sep-15
Bain, BarbaraKingston, ON28-Sep-15
Kristensen, VirginiaOttawa, ON28-Sep-15
Wareham, Janie LouiseScarborough, ON28-Sep-15
Pearce, WilliamSutton West, ON28-Sep-15
Pearce, BarbaraSutton West, ON28-Sep-15
Vincent, JudyOttawa, ON28-Sep-15
Vincent, VadenOttawa, ON28-Sep-15
Jennings, LarryScarborough, ON28-Sep-15
Jennings, RoxanneScarborough, ON28-Sep-15
Osborne, MarieToronto, ON28-Sep-15
Simms, DonnaBrantford, ON28-Sep-15
Simms, GuyBrantford, ON28-Sep-15
Woods, DarrenLondon, ON28-Sep-15
Woods, DanetteLondon, ON28-Sep-15
Coles, BrianKitchener, ON28-Sep-15
Coles, DeborahKitchener, ON28-Sep-15
Crabb, MarkOakville, ON28-Sep-15
Crabb, WendyOakville, ON28-Sep-15
Randell, LisaNiagara Falls, ON28-Sep-15
Randell, RandyNiagara Falls, ON28-Sep-15
Kerr, RobertThunder Bay, ON28-Sep-15
Kerr, ShelleyThunder Bay, ON28-Sep-15
Bamford, Darlene ElizabethAlmonte, ON29-Sep-15
Barber, ElaineMaple Lear, ON29-Sep-15
Huntly, Roy CHarrowsmith, ON29-Sep-15
Storring, Laurie AnnPalmer Rapids, ON29-Sep-15
Whetung, Murray MacKenzieCurve Lake, ON29-Sep-15
Alston, Harold JKingston, ON29-Sep-15
Anderson, Donald JRenfrew, ON29-Sep-15
Begbie, J MichaelPeterborough, ON29-Sep-15
Bresnaham, William AGananoque, ON29-Sep-15
Brown, Glenn RPickering, ON29-Sep-15
Davidson, David DBrockville, ON29-Sep-15
Hobbs, Richard SLindsay, ON29-Sep-15
McBride, H GraceKingston, ON29-Sep-15
Melanson, DavidKingston, ON29-Sep-15
Moses, John WilliamWhitby, ON29-Sep-15
Shepherd, David WCampbellford, ON29-Sep-15
Whiston, Marlene APort Hope, ON29-Sep-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G596)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 1 octobre 2015 au 2 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Roeder Martin, VictoriaSprucedale, ON01-Oct-15
Mundala, Michaux LutlulaRockland, ON01-Oct-15
Mayer, SheliaGuleph, ON01-Oct-15
Hope, Kim S.J.Courtice, ON01-Oct-15
Clark, Jacqueline LBrampton, ON01-Oct-15
Cook, Monika LNapanee, ON01-Oct-15

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 1 octobre 2015 au 2 octobre 2015

DateNomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Du 7 octobre 2015 au 11 octobre 2015Bazen, Peter LPicture Butte, AB01-Oct-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 1 octobre 2015 au 2 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Rosien, SandeeArnpror, ON01-Oct-15
Ezeakacha, Ignatius ChukwumaToronto, ON02-Oct-15
Kulanjiyil, Joy AbrahamMississauga, ON02-Oct-15
Skiba, MichalScarborough, ON02-Oct-15
Troya Acosta, Carlos AndresToronto, ON02-Oct-15
Dovey, Donald WilliamSt Catharines, ON02-Oct-15
Pasternak, StephenEtobicoke, ON02-Oct-15
Crawford, GeorgeMcKellar, ON02-Oct-15
Shearman, DavidOwen Sound, ON02-Oct-15
Cable, PhilipBarrie, ON02-Oct-15
Hunt, RobertHolland Landing, ON02-Oct-15
Houston, JohnNewmarket, ON02-Oct-15
Rennett, WayneOrillia, ON02-Oct-15
Perigoe, Lillian CToronto, ON02-Oct-15
McLeish, J. WayneBurlington, ON02-Oct-15
Gast, Paul WesleyStrathroy, ON02-Oct-15
Dufraimont, LisaKingston, ON02-Oct-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G597)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 5 octobre 2015 au 9 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Ropp, Brenda IWaterloo, ON05-Oct-15
Reid, Robert AToronto, ON05-Oct-15
Kettle, James RDover Center, ON07-Oct-15
Wilkinson, Janice MEldorado, ON07-Oct-15
Khalala, PitchouOttawa, ON07-Oct-15
Wright, Gordan AKitchener, ON07-Oct-15
Henderson, Dugald RobertKingston, ON09-Oct-15
Mercer, BruceKingston, ON09-Oct-15
Mercer, NatalieKingston, ON09-Oct-15
Gushue, PatrickOakville, ON09-Oct-15
Whelan, Dorothy PRichmond, ON09-Oct-15
Okpe, Balonwu AugustinePeterborough, ON09-Oct-15
Dault, MichelSudbury, ON09-Oct-15
Fong, AndreaSudbury, ON09-Oct-15

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 5 octobre 2015 au 9 octobre 2015

DateNomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Du 22 octobre 2015 au 26 octobre 2015Dyck, Henry FPortage la Prairie, MB08-Oct-15
Du 28 janvier 2016 au 1 février 2016Cassidy, Paul CliffordKelowna, BC08-Oct-15
Du 22 octobre 2015 au 26 octobre 2015Payant, Jean-MarieSt-Hyactinthe, QC08-Oct-15
Du 15 décembre 2015 au 19 décembre 2015Ouwehand, Rudy WAbbotsford, BC08-Oct-15
Du 3 décembre 2015 au 7 décembre 2015Oussoren, Aalbertinus Hermen HarryToronto, ON08-Oct-15
Du 29 octobre 2015 au 2 novembre 2115Strachan, James JPonoka, AB08-Oct-15
Du 9 octobre 2015 au 13 octobre 2015Peiser, Allison JNewton, MA09-Oct-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 5 octobre 2015 au 9 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Cottrill, RobertElmira, ON06-Oct-15
Khandani, FariborzNewmarket, ON06-Oct-15
Gurka, EmilPort Colbourne, ON06-Oct-15
Juthman, RalphHavelock, ON09-Oct-15
Gallimore, Sonia BeverlyWaterloo, ON09-Oct-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G598)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 12 octobre 2015 au 16 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Potvin, MarcToronto, ON14-Oct-15
Couture, DanielToronto, ON14-Oct-15
Huffman, Holly RPark Hill, ON14-Oct-15
McIntyre Garrick, Erin JanetDryden, ON14-Oct-15
Smith, Lesli KarenLancaster, ON14-Oct-15
Pero, CraigNapanee, ON14-Oct-15
Pero, TinaNapanee, ON14-Oct-15
Waterman, Nancy NelleneLondon, ON15-Oct-15
McKean, James HartleyOrillia, ON16-Oct-15
Eze, Justin ChukwudubemRed Lake, ON16-Oct-15
Kana, TomasToronto, ON16-Oct-15
Bowman, Les GNew Hamburg, ON16-Oct-15
Watler, Kevin ECambridge, ON16-Oct-15

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 12 octobre 2015 au 16 octobre 2015

DateNomLieuDate d’Entrée en Vigueur
22 octobre 2015 au 26 octobre 2015Jerge, MarieFayetteville, NY15-Oct-15
12 novembre 2015 au 16 novembre 2015VanSloten, JohnCalgary, AB15-Oct-15
31 décembre 2015 au 4 janvier 2016Matthew D VandenHeuvelCalgary, AB15-Oct-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 12 octobre 2015 au 16 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Thompson, Gregory FStittsville, ON15-Oct-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G599)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 19 octobre 2015 au 23 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
McLeod, MargaritaBrampton, ON19-Oct-15
Soosaipillai, ManuelpillaiStevensville, ON19-Oct-15
Fontans, LuigiEcho Bay, ON19-Oct-15
Batsakakis, ChirstoCampbellville, ON19-Oct-15
Maynard, Jay ArthurSmithville, ON19-Oct-15
Freisen, AbrahamStaples, ON19-Oct-15
Stutzman, Noah LCharlton, ON19-Oct-15
Miano, Romeo PNorth York, ON20-Oct-15
Kirika, SerahNewmarket, ON20-Oct-15
Bekkers-Boyd, DonnaManotick, ON20-Oct-15
Bostock, AlexanderBobcaygeon, ON20-Oct-15
Aratryn, AlicjaMississauga, ON20-Oct-15
Wentworth, NormaPickering, ON20-Oct-15
Ysrayl, AriyahlaRichmond, ON20-Oct-15
Ysrayl, ShemuyahRichmond, ON20-Oct-15
Parachin, DonnaKing, ON20-Oct-15
Molenda, Bogdan JChatham, ON20-Oct-15
Greenspan, Ruth EvelynHamilton, ON21-Oct-15
Tudor, Ryan ScottMississauga, ON21-Oct-15
Clermont, Shirley MHawkesbury, ON22-Oct-15
Benz, Randal SBaltimore, ON22-Oct-15
Granata, PasqualinoBrampton, ON22-Oct-15
Frederick, Amanda M HBarrie, ON22-Oct-15
MacLeod, Marlice HTimmins, ON22-Oct-15
Bisnauth, Lloyd ChandilallHamilton, ON22-Oct-15
Ratcliff, Kathy MLondon, ON22-Oct-15
Louissaint, GinoGatineau, QC22-Oct-15
De Smit, DavidLondon, ON23-Oct-15
Haghiri, BehniaKingston, ON23-Oct-15
Bhimji, RosinaKingston, ON23-Oct-15
Abbott-Lennox, Elizabeth LynnOrillia, ON23-Oct-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 19 octobre 2015 au 23 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Smith Good, MarthaNew Hamberg, ON19-Oct-15
MacPherson, VictoriaBrampton, ON20-Oct-15
MacPherson, Arthur ThomasBrampton, ON21-Oct-15
McCracken, Fredrick E.Athens, ON21-Oct-15
Snider, Glen A.Lyn, ON21-Oct-15
Bahr, FrankHamilton, ON21-Oct-15
Lang, BarryHanover, ON21-Oct-15
Beaulne, IsabelLimoges, ON21-Oct-15
Cameron, SherryCalabogie, ON21-Oct-15
Evans, SamanthaOttawa, ON21-Oct-15
Huhges, Natalie Anthonis AdrianaSt. George, ON21-Oct-15
Pouzar, Peter JAjax, ON21-Oct-15
Sharpe, ChristineLondon, ON21-Oct-15
Wood, DarrenKinburn, ON21-Oct-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G600)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 26 octobre 2015 au 30 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Cheriaveliyil Dominic, John FrancisToronto, ON26-Oct-15
Duong, VincentToronto, ON26-Oct-15
Kachappilly George, JojoToronto, ON26-Oct-15
Kannanmangalamnikarth Thomas, SajimonBarrie, ON26-Oct-15
Maksenuk, LisaSt. Catharines, ON26-Oct-15
Roberts, Mark GNew Market, ON26-Oct-15
Stokes, Andy H.S.Barrie, ON26-Oct-15
Wilmering, David AWaterloo, ON26-Oct-15
Head, Lori-LynnMinesing, ON27-Oct-15
Wong, KatherineMississauga, ON27-Oct-15
Paskins, Frances G.Echo Bay, ON27-Oct-15
Hutton, ChrisSt. Catharines, ON27-Oct-15
Vanderveer, Danny EHuntsville, ON27-Oct-15
Van Dyk, DebraleeSt. Catharines, ON27-Oct-15
McCready, Steven TSt. Thomas, ON28-Oct-15
Rudd, Ronald LGreely, ON28-Oct-15
Peever, Doreen MSt. Catharines, ON28-Oct-15
Galazen, AllenOttawa, ON28-Oct-15
Anthony, James EziashiAncaster, ON29-Oct-15
Chan, DerekToronto, ON29-Oct-15
Turner, Edward PPembrooke, ON30-Oct-15
Glagau, Kevin RMississauga, ON30-Oct-15
Stuart, AndrewMarkham, ON30-Oct-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 26 octobre 2015 au 30 octobre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Langevin, Bruce JohnHaley Station, ON26-Oct-15
McRae, William John DougalApsley, ON26-Oct-15
Pilgrim, DouglasRenfrew, ON26-Oct-15
Rakich, JohnTottenham, ON26-Oct-15
Rakich, CarrieTottenham, ON26-Oct-15
Nejati, MitraBrampton, ON27-Oct-15
Weaver, DavidCambridge, ON27-Oct-15
Oliver, MollyWallaceburg, ON28-Oct-15
Hill, Veronica MaySharon, ON28-Oct-15
Biggs, Bonnie LauraFort Erie, ON28-Oct-15
Biggs, DarrellFort Erie, ON28-Oct-15
Mayer, Louise CFalconbridge, ON28-Oct-15
Starks, GailSudbury, ON28-Oct-15
Fraser, Andrew SBurlington, ON29-Oct-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G601)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 2 novembre 2015 au 6 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Davis, Kenneth OPerth, ON02-Nov-15
Smith, JonathanToronto, ON02-Nov-15
Takeda, Barbara AAjax, ON02-Nov-15
Langley, Lorna PWindsor, ON02-Nov-15
Mathew, Mathew NOttawa, ON02-Nov-15
Hildesham, Chaim LeibThornhill, ON02-Nov-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 2 novembre 2015 au 6 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Groff, Irene FBrantford, ON02-Nov-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G602)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 9 novembre 2015 au 13 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Tute, John BernardToronto, ON13-Nov-15
Brockman, RobertGeorgetown, ON13-Nov-15
Head, Sharon ESt.Clements, ON13-Nov-15
Head, Joshua PSt.Clements, ON13-Nov-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 9 novembre 2015 au 13 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Kuriakose, DaijuToronto, ON10-Nov-15
Timm, ChristopherKitchener, ON10-Nov-15
Wayow, PeterDundalk, ON10-Nov-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G603)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 16 novembre 2015 au 20 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Gerber, ShannaMidhurst, ON16-Nov-15
Ambrosio, Siegmund CabaccangWindsor, ON16-Nov-15
Bailey, JoleneOsgoode, ON16-Nov-15
Prevost, Penny Lee AnnLimoges, ON16-Nov-15
Newell, Elizabeth JaneAncaster, ON16-Nov-15
Lund, Michael DArnprior, ON16-Nov-15
Attagutsiak, AigahOttawa, ON16-Nov-15
Mills, Cecil VernonNorth York, ON17-Nov-15
Douglas, Valda KNewmarket, ON17-Nov-15
Limmer, JonathanPentanguishene, ON17-Nov-15
Weber, John MMassey, ON17-Nov-15
Stevens, Terry DMissisauga, ON17-Nov-15
Moore, Richard RobertCochrane, ON18-Nov-15
Melad, Markos YoussefToronto, ON18-Nov-15
DeWolfe, Donald LaurenceToronto, ON18-Nov-15
Joseph, JoseMississauga, ON18-Nov-15
Bedzinski, RobertOshawa. ON18-Nov-15
Parnis, EmanuelToronto, ON18-Nov-15
Nemeth, Wendy AnnOrillia, ON18-Nov-15
Louwerse, John DHamilton, ON18-Nov-15
Gill, Kulbir SinghBrampton, ON19-Nov-15
Goldberg, Aviva RaeToronto, ON19-Nov-15
Kaufman, Audrey RThornhill, ON19-Nov-15
Hancock, LizaWoodville, ON20-Nov-15
Pineros, CesarOttawa, ON20-Nov-15
Best, Franklin RooseveltScarborough, ON20-Nov-15
Do, Tien DuyOttawa, ON20-Nov-15
Lajeunesse, David JamesNepean, ON20-Nov-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 16 novembre 2015 au 20 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Smith, Annette DOshawa, ON16-Nov-15
Witten, Clarence HMorrisburg, ON16-Nov-15
Pot, James EDundas, ON16-Nov-15
Ritsema, KennethPeterborough, ON16-Nov-15
Saundeerson, RoyKingsville, ON16-Nov-15
Maddocks, PeterChatham, ON17-Nov-15
Merritt, Randolph LeylandNorth York, ON17-Nov-15
Bryne, Kevin FrancisKitchener, ON17-Nov-15
Zapata Bejarano, Washington VinicioToronto, ON19-Nov-15
Borg, CarmeloToronto, ON19-Nov-15
Sikora, Jozef DominikToronto, ON19-Nov-15
Rosinski, MarcinToronto, ON19-Nov-15
Tingley, Mary LSt Catharines, ON19-Nov-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G604)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Mohammadi, Ali MazarOttawa, ON23-Nov-15
Juma, SalimOttawa, ON23-Nov-15
Trynoga, RomanMississauga, ON23-Nov-15
Singh, JosephEtobicoke, ON23-Nov-15
McInnes, Gregory JamesAjax, ON23-Nov-15
MacMillan, RobertCornwall, ON25-Nov-15
Kelly, JoshuaToronto, ON25-Nov-15
Weatherdon, BrianDundas, ON26-Nov-15
Garreton, Jose LuisMississauga, ON26-Nov-15
Ko, Byung (James) YunKapuskasing, ON26-Nov-15
Nickel, Brenna LeaOakville, ON26-Nov-15
Glidden, David SWelland, ON26-Nov-15
Lock, Jason R WMarkham, ON26-Nov-15
Meyer, Daniel RBurlington, ON26-Nov-15
Gaskin, Melanie RoannaBrampton, ON27-Nov-15
Lau, Patrick Yuk-LamScarborough, ON27-Nov-15

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015

DateNomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Du 28 janvier 2016 au 1 février 2016Permann, Joshua T DEstevan, SK24-Nov-15
Du 4 février 2016 au 8 février 2016Firszt, Mariusz PPietra Ligure, Italy24-Nov-15
Du 3 décembre 2015 au 7 décembre 2015Duggan, James MGlasgow, Scotland24-Nov-15
Du 29 décembre 2015 au 2 janvier 2016Roy, John MSaint John, NB24-Nov-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Ebofin, Richard ODon Mills, ON23-Nov-15
Bagnall, StephenNorth York, ON23-Nov-15
Buckley, JeffreyInnerkip, ON23-Nov-15
Eckhardt, WalterWaterloo, ON23-Nov-15
Hobson, SeanBaden, ON23-Nov-15
Oduro, PeterKitchener, ON23-Nov-15
Wiesel, John FCambridge, ON23-Nov-15
Lockhart, BonnyPort Perry, ON25-Nov-15
Hopps, James DApsley, ON25-Nov-15
Checketts, Neil PBurlington, ON26-Nov-15
Gregerson, Bruce EdwardPlagrave, ON27-Nov-15
Jones, Gary OTamworth, ON27-Nov-15
Obedkoff, VictoriaToronto, ON27-Nov-15
Thom, TerryRichmond, ON27-Nov-15
Zhang, HaoScarborough, ON27-Nov-15
Draffin, Samuel WarnockLanark, ON27-Nov-15
Waite, JohnOrillia, ON27-Nov-15
Smith, MargaretMidhurst, ON27-Nov-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G605)

Les Certificats D’enregistrement Permanent autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 30 novembre 2015 au 30 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Goodwin, Donald ArthurKingston, ON30-Nov-15
Bentley, Blake OScarborough, ON30-Nov-15
Stanley, StevenPetrolia, ON30-Nov-15
King, David AnthonyScarborough, ON30-Nov-15
King, Janine SScarborough, ON30-Nov-15

Les Certificats D’enregistrement Temporaire autorisant à célébrer des mariages en Ontario ont été délivrés aux suivants :

Du 30 novembre 2015 au 30 novembre 2015

DateNomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Du 2 juin 2016 au 6 juin 2016Kenneth BombayBrantford, ON30-Nov-15
Du 23 décembre 2015 au 27 décembre 2015David FielderWinnipeg, MB30-Nov-15

Les Avis de Radiation de personnes autorisées à célébrer des mariages en Ontario ont été envoyés à :

Du 30 novembre 2015 au 30 novembre 2015

NomLieuDate d’Entrée en Vigueur
Reimers, MarilynBelleview, ON30-Nov-15
Bishop, Bruce EricAmherstburg, ON30-Nov-15
Murray, Scott William ArthurIngersoll, ON30-Nov-15
Miller, PattiMontreal, QC30-Nov-15
Mencia, Juan FranciscoFonthilll, ON30-Nov-15

Alexandra Schmidt
Registraire générale adjointe de l’état civil
(148-G606)